Similar
The remains of Samuel Gray, Samuel Maverick, James Caldwell, Crispus Attucks and Patrick Carr, victims of the Boston Massacre, March 5th 1770, were here interred by order of the Tow - 6e15303f0d9d4aaaf9340a7d755b5a77
2010-05-21 Minden Schwichow Denkmal (6)
ANC Explorer Alfred M. Pride grave
Base of the Cogswell Temperance Fountain, placed in Pawtucket, Rhode Island in 1880
Cope's Bridge, State Route 162, spanning Brandywine Creek (East Bradford Township), Copesville, Chester County, PA
Craigmillar and its environs; with notices of the topography, natural history, and antiquities of the district (1892) (20703068705)
Monument war memorial memorial building. A couple of pots with flowers in them
Thomas Russell's family tomb, built 1810 - Old Burying Ground - Arlington, MA - DSC03055
A stone monument with a plaque on it. Socket pillar el sounjarello.
Related
Denkmal auf der ursprünglichen Grenzlinie von 1833 errichtet, Position verifiziert am 30. Januar 1914
Monument "B" auf der ursprünglichen Grenzlinie, Originalsatz September 1802, Reset 20. Januar 1841, Positionsverifizierung 2. Februar 1914
Monument dédié à la Nation, 31 mai 1792
The Monument in 1830 - Charleston, Boston Mass.
Monument dédié à la Nation, 31 mai 1792
Monument dédié à la Nation, 31 mai 1792
Monument dédié à la Nation, 31 mai 1792
Monument dédié à la Nation, 31 mai 1792
The Monument in 1837 - Charleston, Boston Mass.
Denkmal auf der ursprünglichen Grenzlinie von 1833 errichtet, Position verifiziert am 30. Januar 1914
Zusammenfassung
Fotos vom Bau und der Reparatur von Gebäuden, Einrichtungen und Schiffen in der New Yorker Navy Yard
Nichts gefunden.
Tags
Monument
Original
Grenze
Leitung
ursprüngliche Grenzlinie
New York
New Yorker Marinehof
Schiffbau
hohe Auflösung
Friedhof
Grabdenkmäler
Grab
uns Nationalarchive
Datum
30/01/1914
Quelle
The U.S. National Archives
Link
Copyright-info
No known copyright restrictions